Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

TOITURE SERVICE  SCOO
BINCHE
429.582.712
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
1986-10-31 / 124



ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 27.09.88 - 88227-1085-012
1988 / 114070


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 05.03.90 - 90019-5099-013
1990 / 013520


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 10.08.90 - 90255-5167-012
1990 / 128368


AVENUE CHARLES DELIEGE 91BIS 7130 BINCHE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 25.11.91 - 92006-3560-015
1992 / 008178


TOITURE SERVICE  SPRL
BINCHE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.91, APP 25.01.93 - 93053-1825-013
1993 / 027902


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 17.09.93 - 93427-2588-014
1993 / 178831


MODIFICATION FORME JURIDIQUE - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
1993-04-20 / 123


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 21.09.94 - 94447-3622-014
1994 / 187729


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 14.06.95 - 95313-4350-015
1995 / 090723


AVENUE CHARLES DELIEGE 91BIS 7130 BINCHE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 19.06.96 - 96213-3735-014
1996 / 088200


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.96, APP 18.06.97 - 97300-2350-017
1997 / 116555


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.97, APP 17.06.98 - 98194-4330-016
1998 / 079231


AVENUE CHARLES DELIEGE 91 BIS 7130 BINCHE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 16.06.1999 - 99314-1703-016
1999-07-17 / 0122921


SIEGE SOCIAL
1999-08-04 / 423      BILD


AVENUE MARIE JOSEE 72 7130 BINCHE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 31.08.2000 00592-2672-014
2000-10-03 / 0206830


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 20.06.2001 01301-0130-015
2001-07-05 / 0108660


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 19.06.2002 02300-1991-015
2002-07-04 / 0107323


DEMISSIONS, NOMINATIONS
2002-07-25 / 319      BILD


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 18.06.2003 03345-2765-015
2003-07-09 / 0123218


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 16.06.2004, DPT 02.08.2004 04575-2011-014
2004-08-10 / 0204062


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 28.06.2005 05354-0772-015
2005-06-30 / 0124910


CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …)
2005-10-28 / 0154850      BILD


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 04.07.2006 06401-4733-016
2006-07-06 / 0137611


SIEGE SOCIAL
2007-06-08 / 0081501      BILD


AVENUE LEOPOLD III 26 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE
ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 24.07.2007 07443-0146-017
2007-07-27 / 0170460


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 23.06.2008 08257-0291-017
2008-06-26 / 0103717


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 22.06.2009 09255-0101-017
2009-06-23 / 0102308


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.06.2010, DPT 16.06.2010 10177-0217-016
2010-06-17 / 0094627


DEMISSIONS, NOMINATIONS
2010-08-18 / 0123248      BILD


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 22.06.2011 11184-0127-017
2011-06-23 / 0104813


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 22.06.2012 12194-0319-017
2012-06-26 / 0113573


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 13.06.2013 13170-0061-016
2013-06-14 / 0096722


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 15.04.2014 14091-0217-018
2014-04-16 / 0054249


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 09.06.2015 15154-0435-017
2015-06-10 / 0087775


ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 01.07.2016 16270-0185-015
2016-07-08 / 0156278


SIEGE SOCIAL
2019-01-16 / 2019200127      BILD


RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2019-04-29 / 120977      BILD

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Ouverture de la faillite de : TOITURE SERVICE SPRL AVENUE LEOPOLD III, 26, 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE.
Numéro d'entreprise : 0429.582.712
Référence : 20190097.
Date de la faillite : 15 avril 2019.
Juge commissaire : BRUNO FALLY.
Curateur : PIERRE GILLAIN, RUE TUMELAIRE 23, BTE 011, 6000 CHARLEROI- pierre.gillain@gillain-avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 15/04/2019
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 juin 2019.
Pour extrait conforme : Le curateur : GILLAIN PIERRE.



RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
2021-03-22 / 110767      BILD

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Ouverture de la faillite de : TOITURE SERVICE SPRL AVENUE LEOPOLD III, 26, 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE.
Numéro d'entreprise : 0429.582.712
Référence : 20190097.
Date de la faillite : 15 avril 2019.
Juge commissaire : BRUNO FALLY.
Curateur : PIERRE GILLAIN, RUE TUMELAIRE 23, BTE 011, 6000 CHARLEROI- pierre.gillain@gillain-avocat.be.
Date provisoire de cessation de paiement : 15/04/2019
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 juin 2019.
Pour extrait conforme : Le curateur : GILLAIN PIERRE.

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.
Clôture par liquidation de la faillite de : TOITURE SERVICE SPRL AVENUE LEOPOLD III, 26, 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE.
déclarée le 15 avril 2019.
Référence : 20190097.
Date du jugement : 19 novembre 2020.
Numéro d'entreprise : 0429.582.712
Liquidateur(s) désigné(s) :
TREZEGNIES SYLVIE RUE PASTEUR 89 F-59600 GOGNIES-CHAUSSEE (FRANCE)
Pour extrait conforme : Le curateur : GILLAIN PIERRE.